Parole Eligibility Notice
dte_publ_date: 11-MAR-24
sysdate: 11-MAR-24 10:44:54
Burlington County
NAME/ JAIL
CREDIT
DATE OF 
SENTENCE
JUDGE SENTENCE
BOUNTE, Success   #P1323755   02-14-2024
HAINES 3 years   206
LOCATION   Burlington County Jail
OFFENSE Ind.# 23-11-1428-A Burglary - 3rd Degree, 3 years  
Ind.# 23-09-1200-A Theft By Unlawful Taking - 3rd Degree, 3 years  c/c 
  Burglary - 3rd Degree, 3 years  c/c 
  Credit Card Theft - 4th Degree, 3 years  c/c 
CLEMONS, Roszetta   #P1313276   04-14-2023
BRELAND 4 years  c/c  117
AKA NAME  JACKSON, Mary 
LOCATION   Garden State Reception/Youth Correctional Facility
OFFENSE Ind.# 22-08-1316 Theft By Unlawful Taking - 3rd Degree, 4 years  
*** See ATLANTIC County ***
DAVIS, Azikiwe   #P1323457   02-02-2024
NOCELLA 3 years   182
AKA NAME  DAVIS, Azikawe J 
LOCATION   Camden County Jail
OFFENSE Ind.# 22-03-372 Eluding Police - 3rd Degree, 3 years  
*** See CAMDEN County ***
HARRIS, Anthony   #P1196418   02-02-2024
COOK 8 years , 6 years 9 months 19 days M/M  1088
AKA NAME  TAYLOR, Anthony 
LOCATION   Burlington County Jail
OFFENSE Ind.# 18-09-1246 Manslaughter - 2nd Degree, 8 years , 6 years 9 months 19 days M/M 
Note 1:  
1358 days credit for time served 
PIZARRO, Jonti   #P1322963   01-17-2024
HAINES 4 years   127
LOCATION   Mid-State Correctional Facility
OFFENSE Ind.# 23-12-1487-A Luring/Enticing Child by Various Means - 2nd Degree, 4 years  
SIZEMORE, John   #P1036418   05-13-2016
HAINES 5 years , 4 years 3 months  M/M PV  227
AKA NAME  SIZEMORE, Jay 
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Armed Robbery - 1st Degree, 5 years , 4 years 2 months 30 days M/M 
Ind.# 16-02-167
Note 1: 4 years 3 months  mandatory minimum placed on sentence.
Note 2:  mandatory minimum placed on Ind.# 16-02-167
RELEASED 12-28-19, REVOKED 11-15-23, RET CUSTODY 10-06-23

Parole Eligibility Notice
dte_publ_date: 11-MAR-24
sysdate: 11-MAR-24 10:44:54
Burlington County
NAME/ JAIL
CREDIT
DATE OF 
SENTENCE
JUDGE SENTENCE
TAYLOR, Charles   #P1010380  (1) 02-05-2016
COVERT 7 years , 5 years 11 months 11 days M/M PV  302
AKA NAME  TAYLOR, Omar 
LOCATION   East Jersey State Prison
OFFENSE Ind.# 15-08-996-A Robbery - 2nd Degree, 7 years , 5 years 11 months 11 days M/M 
Ind.# 14-12-1267 Eluding Police - 3rd Degree, 4 years  c/c 
Note 1: 5 years 11 months 11 days mandatory minimum placed on sentence.
Note 2:  mandatory minimum placed on Ind.# 15-08-996-
RELEASED 11-04-20, REVOKED 08-02-23, RET CUSTODY 04-01-22
TAYLOR, Charles   #P1010380  (2) 07-07-2023
BRELAND 5 years , 2 years 6 months  M/M c/s  462
AKA NAME  TAYLOR, Omar 
LOCATION   East Jersey State Prison
OFFENSE Ind.# 22-06-1051 Manufacture/Distribute/Dispense CDS - 3rd Degree, 5 years , 2 years 6 months  M/M 
  Unlawful Possession of Weapons - 2nd Degree, 5 years , 1 year  M/M c/c 
WATKINS, Ronnie   #P1302488   01-28-2022
BURKE III 4 years , 1 year 4 months  M/M  109
AKA NAME  LOWE, Ronny 
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 20-01-049 Manufacture/Distribute/Dispense CDS - 3rd Degree, 4 years , 1 year 4 months  M/M 
*** See GLOUCESTER County ***