Parole Eligibility Notice
dte_publ_date: 15-JUL-24
sysdate: 15-JUL-24 10:16:15
Essex County
NAME/ JAIL
CREDIT
DATE OF 
SENTENCE
JUDGE SENTENCE
ARMSTRONG, Quran   #P1328646   06-26-2024
LEATH 4 years   386
AKA NAME  ARMSTRONG, Quaran J 
LOCATION   Essex County Jail
OFFENSE Ind.# 23-07-1456 Theft By Unlawful Taking - 3rd Degree, 4 years  
Ind.# 23-07-1457 Theft By Unlawful Taking - 3rd Degree, 4 years  c/c 
Ind.# 23-12-2373 Burglary - 3rd Degree, 4 years  c/c 
  Theft By Unlawful Taking - 3rd Degree, 4 years  c/c 
  Obstructing an Administrator of the Law - 4th Degree, 1 year 6 months  c/c 
Ind.# 23-12-2372 Burglary - 3rd Degree, 4 years  c/c 
  Theft By Unlawful Taking - 3rd Degree, 4 years  c/c 
BANKSTON, John   #PN64947   07-08-2024
ZUNIC 5 years  c/c  405
AKA NAME  BANKSTON, Johnny P 
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 23-08-1619 Aggravated Assault - 3rd Degree, 5 years  
Ind.# 23-08-1625 Tampering With Witness - 3rd Degree, 5 years  c/c 
Ind.# 23-08-1620 Contempt - 4th Degree, 1 year 6 months  c/c 
*** See OCEAN County ***
CHAMPAGNE, Jaron   #P1328551   07-01-2024
FUENTES 3 years , 1 year  M/M  255
LOCATION   Garden State Reception/Youth Correctional Facility
OFFENSE Ind.# 24-01-069 Unlawful Possession of Weapons - 2nd Degree, 3 years , 1 year  M/M 
CLARK, Shyheim   #P1150522   01-19-2018
ALI 5 years , 4 years 3 months  M/M PV  285
LOCATION   Northern State Prison
OFFENSE Ind.# 17-05-1368 Armed Robbery - 1st Degree, 5 years , 4 years 3 months  M/M 
Note 1: 4 years 3 months  mandatory minimum placed on sentence.
Note 2:  mandatory minimum placed on Ind.# 17-05-1368
RELEASED 02-08-21, REVOKED 06-08-22, RET CUSTODY 10-07-21
COLON, George   #P1149438   01-16-2018
TEARE 5 years 6 months , 4 years 8 months 1 days M/M PV c/c  214
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 17-07-1863 Aggravated Assault - 2nd Degree, 5 years 6 months , 4 years 8 months 1 days M/M 
  Poss Firearm for Unlawful Purpose - 2nd Degree, 3 years 6 months , 3 years 6 months  M/M c/c 
Note 1: 4 years 8 months 1 days mandatory minimum placed on sentence.
Note 2:  mandatory minimum placed on Ind.# 17-07-1863
Note 3:  mandatory minimum placed on Ind.# 
RELEASED 06-15-21, REVOKED 07-10-24, RET CUSTODY 09-01-23
FRANCIS, Kevin   #P1325715   04-17-2024
GIZZO 5 years , 2 years 6 months 17 days M/M  628
AKA NAME  FRANCES, Kevin 
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 22-08-2026 Aggravated Assault - 2nd Degree, 3 years , 2 years 6 months 17 days M/M 
  Eluding Police - 2nd Degree, 5 years  c/c 

Parole Eligibility Notice
dte_publ_date: 15-JUL-24
sysdate: 15-JUL-24 10:16:15
Essex County
NAME/ JAIL
CREDIT
DATE OF 
SENTENCE
JUDGE SENTENCE
GONZALEZ, Bashir   #P1305963   05-20-2022
ROMANYSHYN 5 years , 4 years 3 months  M/M  556
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 21-06-1028  Conspiracy    Murder - 1st Degree, 5 years , 4 years 3 months  M/M 
  Unlawful Possession of Weapons - 2nd Degree, 5 years , 3 years 6 months  M/M c/c 
Ind.# 21-07-1183 Unlawful Possession of Weapons - 2nd Degree, 3 years 6 months , 3 years 6 months  M/M c/c 
Ind.# 21-07-1184 Manufacture/Distribute/Dispense CDS - 3rd Degree, 4 years  c/c 
Ind.# 21-08-1548 Terroristic Threats - 3rd Degree, 3 years  c/c 
$7,500.00 Restitution  
GRIFFITH, Samuel   #P1300158   12-02-2021
CIFELLI 5 years , 4 years 3 months  M/M PV  918
AKA NAME  GRIFFITH, Samuel S 
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 19-09-2666 Aggravated Assault - 2nd Degree, 5 years , 4 years 3 months  M/M 
  EWC/Harm to Child - 2nd Degree, 5 years  c/c 
RELEASED 12-12-23, REVOKED 07-10-24, RET CUSTODY 02-13-24
HOWARD, Christoph   #P895299   08-01-2014
TEARE 10 years , 8 years 5 months 29 days M/M PV  1071
LOCATION   Bayside State Prison
OFFENSE Ind.# 12-06-1475 Manslaughter, 10 years , 8 years 5 months 29 days M/M 
Note  :  mandatory minimum placed on Ind.# 12-06-1475
RELEASED 09-01-23, REVOKED 03-06-24, RET CUSTODY 02-07-24
JOHNSON, Dyjuan   #P1328718   06-28-2024
BATISTA 3 years , 1 year  M/M  294
LOCATION   Essex County Jail
OFFENSE Unlawful Possession of Weapons - 2nd Degree, 3 years , 1 year  M/M 
Ind.# 23-11-2280
  Possession of C.D.S. - 3rd Degree, 3 years  c/c 
  Possession of Prohibited Weapon - 4th Degree, 1 year 6 months  c/c 
MITCHELL, Devonte   #P1299124   10-19-2021
RAVIN 5 years , 1 year  M/M PV  480
AKA NAME  MITCHELL, Davonte D 
LOCATION   Northern State Prison
OFFENSE Ind.# 21-01-063 Unlawful Possession of Weapons - 2nd Degree, 5 years , 1 year  M/M 
  Possession of Prohibited Weapon - 4th Degree, 1 year 6 months  c/c 
RELEASED 04-07-22, REVOKED 09-20-23, RET CUSTODY 04-26-23
RODRIGUEZ, Harold   #P282531   06-21-1996
VOLKERT Life, 30 years  M/M  499
AKA NAME  ALMONDOVAR, Harold 
LOCATION   New Jersey State Prison
OFFENSE Ind.# 1469-4-95 Murder - 1st Degree, Life, 30 years  M/M 
  Robbery - 1st Degree, 20 years , 10 years  M/M c/c 
  Unlawful Possession of Weapons - 3rd Degree, 5 years  c/c 
   Attempted    Murder - 1st Degree, 20 years , 10 years  M/M c/c 
  Robbery - 1st Degree, 20 years , 10 years  M/M c/c 
  Conspiracy - 2nd Degree,  Merged 
  Possession of Weapon for Unlawful Purpose - 2nd Degree,  Merged 

Parole Eligibility Notice
dte_publ_date: 15-JUL-24
sysdate: 15-JUL-24 10:16:15
Essex County
NAME/ JAIL
CREDIT
DATE OF 
SENTENCE
JUDGE SENTENCE
THOMAS, William   #P1123680   07-18-2017
CIFELLI 5 years , 4 years 2 months 28 days M/M PV  298
AKA NAME  THOMAS, William Ewen 
LOCATION   Mid-State Correctional Facility
OFFENSE Ind.# 17-01-255 Armed Robbery - 1st Degree, 5 years , 4 years 2 months 28 days M/M 
Note  :  mandatory minimum placed on Ind.# 17-01-255
RELEASED 05-02-23, REVOKED 06-19-24, RET CUSTODY 02-07-24
TORY, Malik   #P1319182   08-25-2023
ROMANYSHYN 5 years , 1 year  M/M  8
LOCATION   Garden State Reception/Youth Correctional Facility
OFFENSE Ind.# 22-05-1290 Unlawful Possession of Weapons - 2nd Degree, 5 years , 1 year  M/M