Parole Eligibility Notice
dte_publ_date: 15-JUL-24
sysdate: 15-JUL-24 10:16:45
Union County
NAME/ JAIL
CREDIT
DATE OF 
SENTENCE
JUDGE SENTENCE
DAVIS, Wazir   #P1328734   04-08-2024
NIEVES 5 years   473
AKA NAME  DAVIS, Wazir Z 
LOCATION   Hudson County Jail
OFFENSE Ind.# 17-10-2821-Z  VOP Eluding Police - 2nd Degree, 5 years  
ESTEVAO, Alexander   #P1327836   05-10-2024
ROBERTS 1 year   1
AKA NAME  ESTEVAO, Alexander Mariano 
LOCATION   Serving Time Out of State
OFFENSE Poss. W/Intent to Dist./Disp./Manuf. Drug Paraph-4th Deg, 1 year  
Ind.# 24-05-157-A
HAYES, Nasir   #P1099051   03-10-2017
PEIM 6 years , 5 years 1 month 5 days M/M PV  500
AKA NAME  HAYES, Nasir T 
LOCATION   South Woods State Prison
OFFENSE Ind.# 16-07-471 Armed Robbery - 1st Degree, 6 years , 5 years 1 month 5 days M/M 
$50.00 Restitution  
Note  :  mandatory minimum placed on Ind.# 16-07-471
RELEASED 11-09-23, REVOKED 03-20-24, RET CUSTODY 02-08-24
MAISON, Jae'Cion   #P1288179   02-24-2021
DEITCH 5 years , 4 years 3 months  M/M  153
LOCATION   Edna Mahan Correctional Facility for Women
OFFENSE Ind.# 21-01-010-A Aggravated Assault - 2nd Degree, 5 years , 4 years 3 months  M/M 
MAYS, Larry JR  #P919334   12-12-2014
DONOHUE 13 years , 11 years 17 days M/M PV  1128
LOCATION   Bayside State Prison
OFFENSE Ind.# 12-01-08 Aggravated Manslaughter - 1st Degree, 13 years , 11 years 17 days M/M 
$5,000.00 Restitution  
Note 1: 11 years 17 days mandatory minimum placed on sentence.
Note 2:  mandatory minimum placed on Ind.# 12-01-08
RELEASED 03-27-22, REVOKED 07-10-24, RET CUSTODY 10-05-23